-
EFFECTIVE DESIGN SOLUTIONS LIMITED - 62 Lauderdale Gardens, Glasgow, G12 9QW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC209842
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 62 Lauderdale Gardens
- Glasgow
- G12 9QW 62 Lauderdale Gardens, Glasgow, G12 9QW UK
Management
- Geschäftsführung
- MEEK, Kenneth James
- MEEK, Lynne Patricia
- Prokuristen
- MEEK, Kenneth James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.08.2000
- Gelöscht am:
- 2021-08-31
- SIC/NACE
- 71111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Kenneth James Meek
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-23
- Letzte Einreichung: 2020-08-09
-
EFFECTIVE DESIGN SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- EFFECTIVE DESIGN SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC209842. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 09.08.2000 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71111" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 62 Lauderdale Gardens erreicht werden.
Jetzt sichern EFFECTIVE DESIGN SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Effective Design Solutions Limited - 62 Lauderdale Gardens, Glasgow, G12 9QW, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EFFECTIVE DESIGN SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-notice-voluntary (2021-06-15) - GAZ1(A)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-18) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-06-09) - DS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-05-07) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-07-04) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-24) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-24) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-27) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-08-28) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-08-28) - CH03
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-09-05) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2015-09-04) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-23) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-08-09) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-12) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-07) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-09-01) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-09-05) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-09-14) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-06-08) - AA
-
legacy (2005-08-17) - 363a
keyboard_arrow_right 2004
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2004-06-25) - AA
-
legacy (2004-09-06) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-11-14) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2003-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-09-02) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2002-06-12) - AA
keyboard_arrow_right 2001
-
legacy (2001-07-03) - 287
-
legacy (2001-09-06) - 363s
-
legacy (2001-07-03) - 288a
-
legacy (2001-07-03) - 288b
keyboard_arrow_right 2000
-
legacy (2000-09-14) - 288b
-
incorporation-company (2000-08-09) - NEWINC
-
legacy (2000-09-14) - 288a