-
P C HIRE CARS LTD - Unit 6, 454 Denmark Street, Glasgow, G22 6DB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC343268
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 6
- 454 Denmark Street
- Glasgow
- G22 6DB
- Scotland Unit 6, 454 Denmark Street, Glasgow, G22 6DB, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- CUNNINGHAM, Andrew
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.05.2008
- Alter der Firma 2008-05-22 16 Jahre
- SIC/NACE
- 77110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Andrew Cunningham
- Mr Andrew Cunningham
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- GLENDALE CONTRACTS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-02-28
- Letzte Einreichung: 2019-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-05-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-06-05
- Letzte Einreichung: 2019-05-22
-
P C HIRE CARS LTD Firmenbeschreibung
- P C HIRE CARS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC343268. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.05.2008 registriert. P C HIRE CARS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GLENDALE CONTRACTS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "77110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.05.2013.Die Firma kann schriftlich über Unit 6 erreicht werden.
Jetzt sichern P C HIRE CARS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: P C Hire Cars Ltd - Unit 6, 454 Denmark Street, Glasgow, G22 6DB, Grossbritannien
- 2008-05-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu P C HIRE CARS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-20) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-19) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-19) - PSC07
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-02-19) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-19) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-20) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2016-01-06) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-06) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-14) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-26) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-26) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-26) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-01) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-06-01) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-04) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-05-03) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-01) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-04-07) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2010-06-04) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2010-06-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-06-08) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-10-27) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-27) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2010-10-30) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2010-09-17) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-06-11) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-08-29) - 288b
-
legacy (2008-08-29) - 288a
-
incorporation-company (2008-05-22) - NEWINC