-
ATHOLL HOMES (SCOTLAND) LTD. - 97 Clydesdale Street, Motherwell, ML1 4JQ, Scotland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC415254
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 97 Clydesdale Street
- Motherwell
- ML1 4JQ
- Scotland 97 Clydesdale Street, Motherwell, ML1 4JQ, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- RITCHIE, James Howe
- RITCHIE, Norman Steven
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.01.2012
- Alter der Firma 2012-01-23 12 Jahre
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ritchie Brothers (Holdings) Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- RITCHIE & BAIRD (SCOTLAND) LTD.
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-16
-
ATHOLL HOMES (SCOTLAND) LTD. Firmenbeschreibung
- ATHOLL HOMES (SCOTLAND) LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC415254. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.01.2012 registriert. ATHOLL HOMES (SCOTLAND) LTD. hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen RITCHIE & BAIRD (SCOTLAND) LTD. ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 97 Clydesdale Street erreicht werden.
Jetzt sichern ATHOLL HOMES (SCOTLAND) LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Atholl Homes (Scotland) Ltd. - 97 Clydesdale Street, Motherwell, ML1 4JQ, Scotland, Grossbritannien
- 2012-01-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ATHOLL HOMES (SCOTLAND) LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-23) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-08-04) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-11-04) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-09-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-30) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-19) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-19) - PSC02
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-11) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-09-22) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-11) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-01) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-18) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-11) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-02-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-07) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-08) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-21) - AP01
-
resolution (2013-01-31) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2013-01-31) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-02-01) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-01-21) - TM01
-
gazette-notice-compulsary (2013-05-31) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name (2013-07-29) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-12-17) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-02-27) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-07-31) - DISS40
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-03-21) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-02-08) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2012-01-31) - TM01
-
incorporation-company (2012-01-23) - NEWINC