-
GROGREEN LTD - 2 Lauderside Lauder Place, East Linton, EH40 3DB, Scotland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC488228
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Lauderside Lauder Place
- East Linton
- EH40 3DB
- Scotland 2 Lauderside Lauder Place, East Linton, EH40 3DB, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- BRAND, Hendrik
- JOHNSON, Paul Robert
- WILLEBOORDSE, Marjolein Helena
- Prokuristen
- BALFOUR, Matthew Philip
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.10.2014
- Alter der Firma 2014-10-06 9 Jahre
- SIC/NACE
- 81300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Feurach Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- TURF & AMENITY SOLUTIONS COMPANY LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-17
- Letzte Einreichung: 2023-05-03
-
GROGREEN LTD Firmenbeschreibung
- GROGREEN LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC488228. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.10.2014 registriert. GROGREEN LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen TURF & AMENITY SOLUTIONS COMPANY LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "81300" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 2 Lauderside Lauder Place erreicht werden.
Jetzt sichern GROGREEN LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Grogreen Ltd - 2 Lauderside Lauder Place, East Linton, EH40 3DB, Scotland, Grossbritannien
- 2014-10-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GROGREEN LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2023-03-08) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-08-02) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-01-16) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-02-10) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-03-08) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2023-03-08) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-08-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-03-08) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-03-09) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-03) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2023-05-30) - AA01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-20) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-01-14) - PSC01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-07) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-04-28) - PSC04
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-03) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-22) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-04-08) - AP03
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-05) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-02) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-11-02) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2018-06-25) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-25) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-03) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-03) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-03) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-10) - AA
-
resolution (2017-05-13) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-01) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-06-15) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-10-06) - NEWINC